Vous êtes sur la page 1sur 25

Amtsblatt

Official Journal
Journal officiel

9 I 2018
September l Jahrgang 41
September l Year 41
Septembre l 41e année

ISSN 1996-7543
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018 September / September / septembre

INHALT CONTENTS SOMMAIRE

VERWALTUNGSRAT ADMINISTRATIVE COUNCIL CONSEIL D'ADMINISTRATION


Zusammensetzung des Composition of the Administrative Composition du Conseil
Verwaltungsrats der Europäischen Council of the European Patent d'administration de l'Organisation
Patentorganisation (Stand: Organisation (as at September 2018) européenne des brevets (situation :
September 2018) septembre 2018) A72

EUROPÄISCHES PATENTAMT EUROPEAN PATENT OFFICE OFFICE EUROPÉEN DES


BREVETS
Mitteilungen des EPA Information from the EPO Communications de l'OEB
Mitteilung des Europäischen Notice from the European Patent Communiqué de l'Office européen des
Patentamts vom 25. Juli 2018 über die Office dated 25 July 2018 concerning brevets, en date du 25 juillet 2018,
Aktualisierung der Richtlinien für die the updating of the Guidelines for concernant la mise à jour des
Prüfung im Europäischen Patentamt Examination in the European Patent Directives relatives à l'examen
Office pratiqué à l'Office européen des
brevets A73
Mitteilung des Europäischen Notice from the European Patent Communiqué de l'Office européen des
Patentamts vom 22. Juni 2018 über Office dated 22 June 2018 concerning brevets, en date du 22 juin 2018,
die Aktualisierung der Richtlinien für the updating of the Guidelines for concernant la mise à jour des
die Recherche und Prüfung im Search and Examination at the Directives relatives à la recherche et à
Europäischen Patentamt als PCT- European Patent Office as PCT l'examen pratiqués à l'Office européen
Behörde (PCT-EPA-Richtlinien) Authority (PCT-EPO Guidelines) des brevets agissant en qualité
d'administration PCT (Directives PCT
de l'OEB) A74
Zugang zum neuen Dienstgebäude Entrance to the new building of the Accès au nouveau bâtiment de l'Office
des Europäischen Patentamts in Den European Patent Office in européen des brevets à La Haye –
Haag – Informationen für Besucher The Hague – information for visitors informations à l'intention des visiteurs
und Teilnehmer an mündlichen and parties attending oral proceedings et des parties qui assistent à une
Verhandlungen procédure orale A75

Vertretung Representation Représentation


Liste der beim EPA zugelassenen List of professional representatives Liste des mandataires agréés près
Vertreter before the EPO l'Office européen des brevets A76

Gebühren Fees Taxes


Hinweise für die Zahlung von Gebüh- Guidance for the payment of fees, Avis concernant le paiement des
ren, Auslagen und Verkaufspreisen expenses and prices taxes, redevances et tarifs de vente A77
VERWALTUNGSRAT
ADMINISTRATIVE COUNCIL
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A72

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: September 2018)


Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at September 2018)
Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (situation : septembre 2018)

Präsident Vizepräsident
Chairman Deputy Chairman
Président Vice-Président
Herr Christoph Ernst, Ministerialdirigent, Mr Josef Kratochvíl, President, Industrial Property
Bundesministerium der Justiz und für Office of the Czech Republic
Verbraucherschutz

Mitgliedstaat Vertreter Stellvertreter


Member state Representative Alternate representative
État membre Représentant Suppléant
AL Albanien Albania Albanie Mr Elvin Lako, General Director, General Directorate Ms Rudina Bollano, Director of Examination
of Industrial Property Directorate, General Directorate of Industrial Property

AT Österreich Austria Autriche Frau Mariana Karepova, Präsidentin, Frau Andrea Scheichl, Vizepräsidentin,
Österreichisches Patentamt Österreichisches Patentamt

BE Belgien Belgium Belgique M. Jérôme Debrulle, Conseiller général, Office de la M. Geoffrey Bailleux, Conseiller, Office de la
Propriété Intellectuelle, Service Public Fédéral Propriété Intellectuelle, Service Public Fédéral
Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie

BG Bulgarien Bulgaria Bulgarie Mr Petko Nikolov, President, Patent Office of the Ms Ofelia Kirkorian-Tsonkova, Vice-President,
Republic of Bulgaria Patent Office of the Republic of Bulgaria

CH Schweiz Switzerland Suisse Mme Catherine Chammartin, Directrice, Institut Herr Alban Fischer, Vizedirektor und Leiter der
Fédéral de la Propriété Intellectuelle Patentabteilung, Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum

CY Zypern Cyprus Chypre Mr Spyros Kokkinos, Registrar of Companies and Ms Stalo Papaioannou, Senior Officer of Registrar of
Official Receiver, Ministry of Energy, Commerce, Companies and Official Receiver, Ministry of Energy,
Industry & Tourism Commerce, Industry & Tourism

CZ Tschechische Czech République Mr Josef Kratochvíl, President, Industrial Property Ms Svĕtlana Kopecká, Director of the International
Republik Republic tchèque Office of the Czech Republic Department, Industrial Property Office of the Czech
Republic

DE Deutschland Germany Allemagne Herr Christoph Ernst, Ministerialdirigent, Frau Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin,
Bundesministerium der Justiz Deutsches Patent- und Markenamt

DK Dänemark Denmark Danemark Mr Sune Stampe Sørensen, Director General, Ms Anne Rejnhold Jørgensen, Director, Policy &
Danish Patent and Trademark Office Legal Affairs, Danish Patent and Trademark Office

EE Estland Estonia Estonie Mr Margus Viher, Director General, Estonian Patent Ms Elle Mardo, Head of the Patent Department,
Office Estonian Patent Office

ES Spanien Spain Espagne Mr José Antonio Gil Celedonio, Director General, Ms Silvia Navares González, Senior Adviser,
Spanish Patent and Trademark Office Spanish Patent and Trademark Office

FI Finnland Finland Finlande Mr Antti Riivari, Director General, Finnish Patent and Mr Jorma Hanski, Director, Patents and Trademarks,
Registration Office Finnish Patent and Registration Office

FR Frankreich France France M. Pascal Faure, Directeur général, Institut National M. Philippe Cadre, Directeur de la propriété
de la Propriété Industrielle (INPI) industrielle, Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI)

GB Vereinigtes United Royaume-Uni Mr Tim Moss, Chief Executive and Comptroller Ms Liz Coleman, Director Patents Policy
Königreich Kingdom General, Intellectual Property Office Intellectual Property Office

GR Ellas Ellas Ellas Mr Prodromos Tsiavos, President of the Mr Ioannis Kaplanis, Director General, Industrial
Administrative Council, Industrial Property Property Organisation (OBI)
Organisation (OBI)

HR Kroatien Croatia Croatie Ms Ljiljana Kuterovac, Director General, State Ms Ana Rački Marinković, Deputy Director General,
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia State Intellectual Property Office of the Republic of
Croatia

HU Ungarn Hungary Hongrie Mr Viktor Łuszcz, President, Hungarian Intellectual Ms Dóra Gyetvainé Virág, Head of Patent
Property Office Department, Hungarian Intellectual Property Office

IE Irland Ireland Irlande Mr Gerard Barrett, Controller, Irish Patents Office Ms Mary Flynn, Higher Executive Officer, Head of
Finance and Customer Service, Irish Patents Office

IS Island Iceland Islande Ms Borghildur Erlingsdóttir, Director General, Ms Elfa Íshólm Ólafsdóttir, Head of Finance and
Icelandic Patent Office Operations, Icelandic Patent Office

1
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A72

Mitgliedstaat Vertreter Stellvertreter


Member state Representative Alternate representative
État membre Représentant Suppléant
IT Italien Italy Italie Mr Mauro Masi, Delegate for Intellectual Property, Ms Loredana Gulino, Director General, General
Directorate General for Global Affairs, Ministry of Directorate for the fight against counterfeiting - Italian
Foreign Affairs Patent and Trademark Office, Ministry for Economic
Development

LI Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein Frau Ute Hammermann, Abteilungsleiterin, Herr Patrick Ritter, Abteilungsleiter, Abteilung
Immaterialgüterrecht, Amt für Volkswirtschaft Wirtschaft und Entwicklung, Amt für Auswärtige
Angelegenheiten

LT Litauen Lithuania Lituanie Mr Arūnas Želvys, Director, State Patent Bureau of Mr Žilvinas Danys, Deputy Director, State Patent
the Republic of Lithuania Bureau of the Republic of Lithuania

LU Luxemburg Luxembourg Luxembourg M. Lex Kaufhold, Conseiller de direction 1ère classe, M. Claude Sahl, Chef du secteur "Législation", Office
Chargé de direction, Office de la propriété de la propriété intellectuelle, Ministère de l'Économie
intellectuelle, Ministère de l'Économie

LV Lettland Latvia Lettonie Mr Sandris Laganovskis, Director, Patent Office of Mr Guntis Ramāns, Director of the Department of
the Republic of Latvia Examination of Inventions, Patent Office of the
Republic of Latvia

MC Monaco Monaco Monaco M. Thomas Lantheaume, Directeur Adjoint, Direction M. Jean-Pierre Santos, Chef de Division, Division de
de l'Expansion Économique la Propriété Intellectuelle, Direction de l'Expansion
Économique

MK ehemalige former ex-République Mr Safet Emruli, Director, State Office of Industrial Mr Jetmir Shabani, Head of Patent Unit, State Office
jugoslawische Yugoslav yougoslave de Property of Industrial Property
Republik Republic of Macédoine
Mazedonien Macedonia

MT Malta Malta Malte Mr Godwin Warr, Director General, Commerce Ms Michelle Bonello, Director, Industrial Property
Department, Comptroller of Industrial Property, Registrations, Commerce Department, Ministry for the
Ministry for the Economy, Investment and Small Economy, Investment and Small Business
Business

NL Niederlande Netherlands Pays-Bas Mr Derk-Jan De Groot, Director, Netherlands Patent Mr Paul Van Beukering, Unit Manager, Ministry of
Office Economic Affairs

NO Norwegen Norway Norvège Mr Per A. Foss, Director General, Norwegian Mr Jostein Sandvik, Director, Legal and International
Industrial Property Office Affairs, Norwegian Industrial Property Office

PL Polen Poland Pologne Ms Alicja Adamczak, President, Patent Office of the Ms Ewa Nizińska Matysiak, Director of the Cabinet
Republic of Poland of the President, Patent Office of the Republic of
Poland

PT Portugal Portugal Portugal Ms Maria Leonor Mendes da Trindade, President of Mr Marco Dinis, Member of the Directive Council,
the Directive Council, National Institute of Industrial National Institute of Industrial Property (INPI)
Property (INPI)

RO Rumänien Romania Roumanie Mr Ionut Barbu, Director General, State Office for Mr Catalin Nitu, Director Legal Department, State
Inventions and Trademarks Office for Inventions and Trademarks

RS Serbien Serbia Serbie Mr Vladimir Marić, Acting Director, Intellectual Ms Mirjana Jelić, Assistant Director of the Patent
Property Office of the Republic of Serbia Sector, Intellectual Property Office of the Republic of
Serbia

SE Schweden Sweden Suède Mr Peter Strömbäck, Director General, Swedish Ms Karin Bergh, Chief Legal Counsel, Swedish
Patent and Registration Office Patent and Registration Office

SI Slowenien Slovenia Slovénie Mr Vojko Toman, Director, Slovenian Intellectual Ms Helena Zalaznik, Head of Patent and SPC
Property Office Section, Slovenian Intellectual Property Office

SK Slowakei Slovakia Slovaquie Mr Richard Messinger, President, Industrial Property Ms Lukrécia Marčoková, Director, Patent
Office of the Slovak Republic Department, Industrial Property Office of the Slovak
Republic

SM San Marino San Marino Saint-Marin Ms Silvia Rossi, Director, State Office for Patents Mr Bruno Cinquantini, Advisor, Secretariat of State
and Trademarks for Industry, Handcraft and Commerce, State Office
for Patents and Trademarks

TR Türkei Turkey Turquie Mr Habip Asan, President, Turkish Patent and Mr Salih Bektaş, Head of Patent Department,
Trademark Office Turkish Patent and Trademark Office

2
EUROPÄISCHES PATENTAMT
EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A73

Mitteilung des Europäischen Notice from the European Patent Communiqué de l'Office
Patentamts vom 25. Juli 2018 Office dated 25 July 2018 européen des brevets, en date
über die Aktualisierung der concerning the updating of the du 25 juillet 2018, concernant la
Richtlinien für die Prüfung im Guidelines for Examination in mise à jour des Directives
Europäischen Patentamt the European Patent Office relatives à l'examen pratiqué à
l'Office européen des brevets
Mit Verfügung des Präsidenten des By decision of the President of the EPO Par décision du Président de l'OEB en
EPA vom 25. Juli 2018 und gemäß dated 25 July 2018 and pursuant to date du 25 juillet 2018 et conformément
Artikel 10 (2) EPÜ wurden die Richtli- Article 10(2) EPC, the Guidelines for à l'article 10(2) CBE, les Directives
nien für die Prüfung im Zuge ihrer Examination have been amended in relatives à l'examen ont été modifiées,
alljährlichen Überarbeitung geändert. line with the EPO's policy of updating en application de la politique de l'OEB
Die neuen Richtlinien, die am them on an annual basis. The amended qui prévoit leur révision sur une base
1. November 2018 in Kraft treten, Guidelines, which will enter into force annuelle. La version modifiée des
werden als vollständige Neufassung on 1 November 2018, will be published Directives entrera en vigueur le
vom November 2018 veröffentlicht und as a complete November 2018 edition 1er novembre 2018 et sera publiée sous
lösen die Richtlinien mit Stand which will supersede the la forme d'une édition complète datée
November 2017 ab. November 2017 edition. du mois de novembre 2018 qui
remplacera l'édition de novembre 2017.
Die Neufassung der Richtlinien wird The new Guidelines will be published Les nouvelles Directives seront
elektronisch publiziert und kann in allen electronically and will be available in all publiées sous forme électronique et
drei Amtssprachen von der EPA- three official languages on the EPO seront accessibles dans les trois
Website (www.epo.org/law- website at www.epo.org/law- langues officielles de l'OEB sur le site
practice/legal-texts/guidelines_de.html) practice/legal-texts/guidelines.html, Internet de l'OEB (à l'adresse suivante :
gebührenfrei heruntergeladen werden. where they can be downloaded free of www.epo.org/law-practice/legal-
In Anbetracht der häufigen Überar- charge. In view of the frequent revision texts/guidelines_fr.html) où elles
beitung der Richtlinien wird die Veröf- of the Guidelines, the print version has pourront être téléchargées
fentlichung in Papierform eingestellt. been discontinued. gratuitement. Compte tenu de la
fréquence des révisions des Directives,
celles-ci ne sont plus imprimées au
format papier.
Um der Allgemeinheit die Änderungen In order to serve the public interest in La version anglaise des Directives sera
so früh wie möglich bekannt zu geben, making the amendments available as prépubliée sur le site Internet de l'OEB
wird bereits im Oktober eine Vorabver- soon as possible, an advance "preview" en octobre, afin que les changements
sion der Richtlinien in englischer version of the Guidelines in English will soient accessibles au public dans les
Sprache auf der Website des EPA ver- be published on the EPO website in meilleurs délais.
öffentlicht. October.
Änderungen wurden in allen acht Teilen Amendments have been made to all Des modifications ont été apportées
der Richtlinien vorgenommen. Eine eight parts of the Guidelines. A number aux huit parties des Directives. Un
Reihe von Änderungen wurden vor dem of amendments have been made in the certain nombre de changements ont été
Hintergrund neuer Entscheidungen der light of decisions of the Enlarged Board effectués à la lumière de décisions de
Großen Beschwerdekammer und der of Appeal and the other boards of la Grande Chambre de recours et des
anderen Beschwerdekammern vorge- appeal. Part A has been updated to autres chambres de recours. La
nommen. Teil A enthält jetzt Informati- include payment by credit card as a partie A a été mise à jour pour inclure le
onen zur Kreditkartenzahlung als neuer new payment method and to reflect the paiement par carte de crédit comme
Zahlungsart und wurde an die geän- changes to the Arrangements for nouveau moyen de paiement et pour
derten Vorschriften über das laufende deposit accounts which entered into tenir compte des modifications de la
Konto angepasst, die am force on 1 December 2017. Part A now réglementation applicable aux comptes
1. Dezember 2017 in Kraft getreten also includes a reference to the courants entrées en vigueur le
sind. Außerdem wird in Teil A jetzt auf validation agreements with Tunisia and 1er décembre 2017. La partie A contient
die am 1. Dezember 2017 bzw. am Cambodia that entered into force on également une référence aux accords
1. März 2018 in Kraft getretenen 1 December 2017 and 1 March 2018 de validation avec la Tunisie et le
Validierungsabkommen mit Tunesien respectively. In Part F, the chapter Cambodge, entrés en vigueur
und Kambodscha verwiesen. In Teil F relating to non-unity, as well as some of respectivement les 1er décembre 2017
wurden das Kapitel über mangelnde the sub-sections addressing clarity of et 1er mars 2018. En ce qui concerne la
Einheitlichkeit und einige Unterpunkte the claims, have been thoroughly partie F, le chapitre relatif à l'absence
zur Klarheit der Ansprüche gründlich revised. The same applies to Part G, d'unité, ainsi que certaines sous-
überarbeitet. Gleiches gilt für Teil G und particularly to the sections in respect of sections traitant de la clarté des
insbesondere für die Abschnitte zur the patentability of mathematical revendications, ont été entièrement
Patentierbarkeit von mathematischen methods and schemes, rules and remaniés. Il en va de même de la
Methoden sowie von Plänen, Regeln methods for performing mental acts, partie G, en particulier des sections
und Verfahren für gedankliche Tätig- playing games or doing business. In relatives à la brevetabilité des
keiten, für Spiele oder für geschäftliche those sections, new sub-sections, e.g. méthodes mathématiques ainsi que des
Tätigkeiten. In diese Abschnitte wurden relating to artificial intelligence and plans, principes et méthodes dans
neue Unterpunkte aufgenommen, z. B. machine learning, have been created to l'exercice d'activités intellectuelles, en
zur künstlichen Intelligenz und zum define the relevant patentability criteria matière de jeu ou dans le domaine des
maschinellen Lernen, um die einschlä- more precisely. Furthermore, a number activités économiques. Dans ces

1
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A73

gigen Patentierbarkeitskriterien genauer of clarifications and updates regarding sections, de nouvelles sous-sections
zu definieren. In den Teilen C, D, E und EPO practice have been added to concernant par exemple l'intelligence
H wurden einige Klarstellungen und Parts C, D, E and H, e.g. addressing artificielle et l'apprentissage
Aktualisierungen hinsichtlich der Praxis the apportionment and fixing of costs in automatique, ont été créées pour définir
des EPA vorgenommen, wie etwa zur opposition proceedings (Part D-IX). plus précisément les critères de
Kostenverteilung und Kostenfest- brevetabilité pertinents. En outre, des
setzung im Einspruchsverfahren clarifications et des informations
(Teil D-IX). actualisées concernant la pratique de
l'OEB ont été intégrées dans les
parties C, D, E et H, par exemple en ce
qui concerne la répartition et la fixation
des frais de la procédure d'opposition
(Partie D-IX).
Darüber hinaus sind in die neue Fas- The new edition of the Guidelines also Enfin, la nouvelle édition des Directives
sung der Richtlinien auch Bemerkungen reflects comments and proposals tient compte de remarques et de
und Anregungen von Nutzern einge- received from users. propositions reçues de la part
gangen. d'utilisateurs.
Eine vollständige Liste der geänderten A full list of the sections which have Une liste complète des sections ayant
Abschnitte mit den entsprechenden been amended, together with fait l'objet de modifications, avec les
Hyperlinks ist auf der EPA-Website zu corresponding hyperlinks, is available hyperliens correspondants, est
finden. Innerhalb jedes Abschnitts der on the EPO website. Within each disponible sur le site Internet de l'OEB.
HTML-Version lassen sich die Änderun- section of the HTML version, the actual Dans chaque section de la version
gen durch Anklicken des Felds "Ände- amendments can be viewed by ticking HTML, il est possible de visionner les
rungen anzeigen" (oben rechts) sicht- the "Show modifications" box in the top modifications en cochant la case
bar machen. Auf der Website sind auch right-hand corner. Versions of the "Montrer les modifications" en haut à
PDF-Versionen der Richtlinien abrufbar, Guidelines in PDF format – including a droite de l'écran. Des versions des
darunter eine Reinschrift und eine Fas- clean copy and a version showing all Directives au format PDF, comprenant
sung, in der alle Änderungen ersichtlich modifications – are also available on une version au propre et une version
sind. the website. faisant apparaître toutes les
modifications, sont également
disponibles sur le site Internet.

2
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A74

Mitteilung des Europäischen Notice from the European Patent Communiqué de l'Office
Patentamts vom 22. Juni 2018 Office dated 22 June 2018 européen des brevets, en date
über die Aktualisierung der concerning the updating of the du 22 juin 2018, concernant la
Richtlinien für die Recherche Guidelines for Search and mise à jour des Directives
und Prüfung im Europäischen Examination at the European relatives à la recherche et à
Patentamt als PCT-Behörde Patent Office as PCT Authority l'examen pratiqués à l'Office
(PCT-EPA-Richtlinien) (PCT-EPO Guidelines) européen des brevets agissant
en qualité d'administration PCT
(Directives PCT de l'OEB)
Mit Verfügung des Präsidenten des By decision of the President of the EPO Par décision du Président de l'OEB en
EPA nach Artikel 10 (2) EPÜ vom dated 22 June 2018 and pursuant to date du 22 juin 2018 et conformément à
22. Juni 2018 wurden die Richtlinien für Article 10(2) EPC, the Guidelines for l'article 10(2) CBE, les Directives
die Recherche und Prüfung im Europä- Search and Examination at the relatives à la recherche et à l'examen
ischen Patentamt als PCT-Behörde European Patent Office as PCT pratiqués à l'Office européen des
(PCT-EPA-Richtlinien) im Zuge ihrer Authority (PCT-EPO Guidelines) have brevets agissant en qualité
alljährlichen Überarbeitung geändert. been amended in line with the EPO's d'administration PCT (Directives PCT
Die geänderten PCT-EPA-Richtlinien, policy of updating them on an annual de l'OEB) ont été modifiées, en
die am 1. November 2018 in Kraft basis. The amended PCT-EPO application de la politique de l'OEB qui
treten, werden als vollständige Neu- Guidelines, which will enter into force prévoit leur mise à jour sur une base
fassung vom November 2018 veröffent- on 1 November 2018, will be published annuelle. La version modifiée des
licht und lösen die Richtlinien mit Stand as a complete November 2018 edition Directives PCT de l'OEB, qui entrera en
November 2017 ab. which will supersede the vigueur le 1er novembre 2018, sera
November 2017 edition. publiée sous la forme d'une édition
complète datée du mois de
novembre 2018 qui remplacera l'édition
de novembre 2017.
Wie die früheren Ausgaben wird auch Like the previous editions, the À l'instar des précédentes versions,
die Neufassung der PCT-EPA- November 2018 edition of the l'édition de novembre 2018 des
Richtlinien vom November 2018 nur PCT-EPO Guidelines will be published Directives PCT de l'OEB sera publiée
elektronisch veröffentlicht und kann in only in electronic form and will be uniquement au format électronique et
allen drei Amtssprachen kostenlos auf available in all three official languages sera accessible dans les trois langues
der EPA-Website abgerufen werden: on the EPO website at officielles de l'OEB sur le site Internet
www.epo.org/law-practice/legal- www.epo.org/law-practice/legal- de l'OEB (à l'adresse suivante :
texts/guidelines-pct_de.html. texts/guidelines-pct.html, where it can www.epo.org/law-practice/legal-
be downloaded free of charge. texts/guidelines-pct_fr.html), où elle
pourra être téléchargée gratuitement.
Um der Allgemeinheit die Änderungen In order to serve the public interest in La version anglaise des Directives PCT
so früh wie möglich bekannt zu geben, making the amendments available as de l'OEB sera prépubliée sur le site
wird bereits im Oktober eine Vorab- soon as possible, an advance "preview" Internet de l'OEB en octobre, afin que
version dieser Richtlinien in englischer version of the PCT-EPO Guidelines in les changements soient accessibles au
Sprache auf der Website des EPA ver- English will be published on the EPO public dans les meilleurs délais.
öffentlicht. website in October.
Änderungen wurden in allen Teilen der Amendments have been made to all Des modifications ont été apportées à
PCT-EPA-Richtlinien vorgenommen. parts of the PCT-EPO Guidelines. The toutes les parties des Directives PCT
Insbesondere wurde Teil A erweitert, major change is the expansion of de l'OEB. La principale modification a
der nunmehr ein Kapitel mit dem Titel Part A, which now includes a chapter consisté à enrichir la partie A, qui
"Sonderbestimmungen" (Kapitel IV) entitled "Special provisions" comprend désormais un chapitre intitulé
umfasst, dessen zwei Unterabschnitte (Chapter IV). This new chapter "Dispositions particulières"
sich mit dem Dienst PCT-Direkt und mit comprises two sections, one dedicated (chapitre IV). Ce nouveau chapitre se
Zurücknahmen befassen. Die übrigen to the PCT Direct service and one to compose de deux parties, l'une
Änderungen in Teil A betreffen vor withdrawals. Other amendments to consacrée au service PCT Direct et
allem die am 1. Dezember 2017 einge- Part A reflect in particular the l'autre aux retraits. Les autres
führte Möglichkeit der Gebührenzah- introduction of credit card as a fee modifications apportées à la partie A
lung per Kreditkarte und die am selben payment method as from ont notamment trait à l'introduction du
Tag in Kraft getretenen Änderungen der 1 December 2017, the changes to the paiement par carte de crédit comme
Vorschriften über das laufende Konto Arrangements for deposit accounts mode de paiement des taxes à compter
sowie die seit 1. April 2018 geltenden which entered into force on the same du 1er décembre 2017, aux
Gebührenänderungen. date and the fee changes which modifications de la réglementation
entered into force on 1 April 2018. applicable aux comptes courants
entrées en vigueur à la même date,
ainsi qu'aux modifications des taxes
prenant effet le 1er avril 2018.

1
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A74

Teil B wurde ebenfalls aktualisiert, um Part B has been updated too, for La partie B a elle aussi été mise à jour,
beispielsweise die Tatsache zu berück- instance to reflect the fact that the notamment afin de refléter le fait que la
sichtigen, dass das allen Recherchen- provision of an information sheet on fiche d'information sur les stratégies de
berichten beigefügte Informationsblatt search strategies with all search reports recherche fournie avec tous les
zur Recherchestrategie seit became a permanent service on rapports de recherche est devenue un
1. Januar 2018 eine dauerhafte Dienst- 1 January 2018. In general, service permanent depuis le
leistung ist. In mehreren Teilen dienen amendments have been made to 1er janvier 2018. De manière générale,
die Änderungen allgemein dazu, die several parts with a view to clarifying des modifications ont été apportées à
Praxis des EPA klarzustellen, beispiels- the EPO's practice, for instance to plusieurs parties en vue de clarifier la
weise in Teil G, wo es um die Beurtei- Part G on the topic of assessing the pratique de l'OEB, par exemple dans la
lung von Offenbarungen durch fehler- disclosure made by prior-art documents partie G, en ce qui concerne
hafte Dokumente des Stands der containing errors. Other amendments l'appréciation des divulgations
Technik geht. Andere Änderungen aim at further improving the text of the effectuées par des documents de l'état
zielen darauf ab, die Vorläuferfassung previous edition or at updating it, for de la technique contenant des erreurs.
weiter zu verbessern oder zu aktuali- instance to include the EPO's new D'autres modifications visent à
sieren, etwa um den neuen PPH- Patent Prosecution Highway partner améliorer encore le texte de l'édition
Partnerämtern des EPA oder der Ände- offices or to reflect changes to the précédente ou à le mettre à jour,
rung geltender Rechtstexte Rechnung applicable legal provisions (e.g. the notamment pour inclure les nouveaux
zu tragen, wie der am 1. Januar 2018 in entry into force on 1 January 2018 of offices partenaires de l'OEB dans le
Kraft getretenen neuen Vereinbarung the new Agreement between the cadre du "Patent Prosecution Highway",
zwischen der Europäischen Patentorga- European Patent Organisation and the ou pour refléter les modifications des
nisation und dem Internationalen Büro International Bureau of the World dispositions juridiques applicables (par
der Weltorganisation für geistiges Intellectual Property Organization in ex. l'entrée en vigueur le
Eigentum über die Aufgaben des EPA relation to the functioning of the EPO as 1er janvier 2018 du nouvel accord entre
als internationaler Behörde nach dem an International Authority under the l'Organisation européenne des brevets
PCT. PCT). et le Bureau international de
l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle concernant les fonctions
de l'OEB en qualité d'administration
internationale au titre du PCT).
Der Inhalt der PCT-EPA-Richtlinien wird The content of the PCT-EPO Le contenu des Directives PCT de
auch künftig bei der nächsten Überar- Guidelines will continue to be expanded l'OEB continuera d'être enrichi lors de
beitung erweitert. in the next revision. la prochaine révision.
Eine vollständige Liste der geänderten A full list of the sections which have Une liste complète des sections ayant
Abschnitte mit den entsprechenden been amended, together with fait l'objet de modifications, avec les
Hyperlinks ist auf der EPA-Website zu corresponding hyperlinks, is available hyperliens correspondants, est
finden. Innerhalb jedes Abschnitts der on the EPO website. Within each disponible sur le site Internet de l'OEB.
HTML-Version lassen sich die Änderun- section of the HTML version, the Dans chaque section de la version
gen durch Anklicken des Felds "Ände- amendments can be viewed by ticking HTML, il est possible de visionner les
rungen anzeigen" (oben rechts) sicht- the "Show modifications" box in the top modifications en cochant la case
bar machen. Zudem werden auf der right-hand corner. On the website there "Montrer les modifications" en haut à
Website zwei PDF-Fassungen bereit- are also two versions in PDF, one droite de l'écran. Les Directives PCT de
gestellt: eine mit sichtbaren Änderun- showing all modifications and one clean l'OEB figurent aussi au format PDF sur
gen und eine Reinschrift. copy. le site Internet dans une version faisant
apparaître toutes les modifications,
ainsi que dans une version au propre.

2
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A75

Zugang zum neuen Entrance to the new building of Accès au nouveau bâtiment de
Dienstgebäude des the European Patent Office in l'Office européen des brevets à
Europäischen Patentamts in The Hague – information for La Haye – informations à
Den Haag – Informationen für visitors and parties attending l'intention des visiteurs et des
Besucher und Teilnehmer an oral proceedings parties qui assistent à une
mündlichen Verhandlungen procédure orale
Ab 8. Oktober 2018 erfolgt der Zugang As of 8 October 2018, the EPO's new À compter du 8 octobre 2018, l'accès
zum neuen EPA-Gebäude in Den Haag building in The Hague will be accessed au nouveau bâtiment de l'OEB à
über den offiziellen Haupteingang in der through the new main entrance on the La Haye se fera par la nouvelle entrée
Veraartlaan, wo sich auch der neue Veraartlaan, where the new visitors' car principale dans la Veraartlaan, où se
Besucherparkplatz befindet. Der park is situated. The entrance to the old trouve également le nouveau parking
Eingang zum alten Hauptgebäude und main building and the temporary visiteurs. L'entrée de l'ancien bâtiment
der provisorische Eingang in der entrance at Van Benthemlaan 16 will be principal et l'entrée provisoire sise Van
Van Benthemlaan 16 werden geschlos- closed. Parties attending oral Benthemlaan 16 seront fermées. Les
sen. Teilnehmer mündlicher Verhand- proceedings must first report to the new parties qui assistent à une procédure
lungen melden sich bei der neuen reception desk and then go through the orale doivent d'abord se signaler au
Empfangsloge an und durchlaufen die usual security checks before heading to nouveau bureau d'accueil et se
üblichen Sicherheitskontrollen, bevor their meeting room. Since the distances soumettre aux contrôles de sécurité
sie sich zu den Verhandlungsräumen to be covered within the new building usuels avant de se rendre dans leur
begeben. Allen Besuchern wird may be longer, visitors are advised to salle de réunion. Comme les distances
empfohlen, ausreichend Zeit für die arrive as early as possible to ensure à parcourir dans le nouveau bâtiment
verschiedenen Wege innerhalb des they have enough time. peuvent être plus grandes, il est
neuen Gebäudes einzuplanen. recommandé aux visiteurs de prévoir
assez de temps pour leurs
déplacements.
Nähere praktische Hinweise enthält die For practical information, consult the D'autres informations pratiques figurent
Website des EPA unter webpages on www.epo.org/service- à l'adresse www.epo.org/service-
www.epo.org/service-support/contact- support/contact-us/the-hague.html. support/contact-us/the-hague_fr.html.
us/the-hague_de.html.
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter1


List of professional representatives before the European Patent Office1
Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets1
Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

AT Österreich Austria Autriche

Eintragungen Entries Inscriptions Filiz, Çiğdem (TR) Gall-Schuhmann, Johannes (AT) Schardmüller, Robert Claudius (AT)
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Lenzing AG Kliment & Henhapel Patentanwälte
Co KG Werkstraße 2 OG
Dr. Boehringer Gasse 5-11 4860 LENZING Singerstraße 8
1121 WIEN 1010 WIEN

von Grafenstein, Susanne (DE)


Schwarz & Partner Patentanwälte
OG
Wipplingerstraße 30
1010 WIEN

Löschungen Deletions Radiations Piso, Eberhard (AT)


R. 154(1)
Barger, Piso & Partner
Patentanwälte
Operngasse 4
1010 WIEN

BE Belgien Belgium Belgique

Eintragungen Entries Inscriptions Coenegrachts, Lieve (BE) Eulaers, Eva (BE) Jacobs, Tinneke Ivonne C (BE)
LC Patents V.O. Patent and Trademarks Bureau M.F.J. Bockstael N.V.
Kempische Steenweg 542 a Gaston Geenslaan 11 B4 Arenbergstraat 13
3500 HASSELT 3001 HEVERLEE 2000 ANTWERPEN

Marcus, Thomas (FR) Preat, Julien (BE) Van den Bosch, Remy (BE)
cf. FR Umicore Arnold & Siedsma
Schneider Electric Services RDI Patent Department Meir 24
International sprl. Watertorenstraat 33 2000 ANTWERPEN
5, place du Champs de Mars 2250 OLEN
1050 BRUXELLES

Van Minnebruggen, Ewan Benito Versaevel, Sebastien (BE) Vinck, Glenn (BE)
Agnes (BE) Mohawk International Services, NLO bvba
Atlas Copco Airpower, N.V. BVBA Technologiepark 19
Airtec Division Ooigemstraat 3 9052 GENT (ZWIJNAARDE)
P.O. Box 101 8710 WIELSBEKE
Boomsesteenweg 957
2610 WILRIJK

Änderungen Amendments Modifications Van Cauteren, Tim (BE)


Ommegangstraat 71
9240 ZELE

BG Bulgarien Bulgaria Bulgarie

Eintragungen Entries Inscriptions Hristova, Lilyana (BG)


RP Partners Ltd.
11, Slaveikov sq., fl.1, office 5
1000 SOFIA

CH Schweiz Switzerland Suisse

Eintragungen Entries Inscriptions Choi, Theodore (CH) Cohen, Nathalie Ann Esther (GB) Ćorić, Dragan (HR)
Rentsch Partner AG Philip Morris Products S.A. General Electric Technology GmbH
Rechtsanwälte und Patentanwälte Quai Jeanrenaud 3 GE Corporate Intellectual Property
Bellerivestrasse 203 2000 NEUCHÂTEL Brown Boveri Strasse 7
Postfach 5400 BADEN
8034 ZÜRICH

Finklenburg, Susanne (DE) Horlacher, Oliver Philip (CH) Ko, Benjamin Hyensuk (DE)
Keller & Partner Patentanwälte AG Patentanwalt Dr. Kasche Isler & Pedrazzini AG
Bahnhofplatz 18 Resirain 1 Giesshübelstrasse 45
8401 WINTERTHUR 8125 ZOLLIKERBERG/ZÜRICH Postfach 1772
8027 ZÜRICH

1 1 1
Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter All persons on the list of professional Toute personne inscrite sur la liste des
eingetragenen Personen sind Mitglieder des representatives are members of the Institute mandataires agréés est membre de l'Institut
Instituts (epi). (epi). (epi).
Anschrift: Address: Adresse :
epi-Sekretariat epi Secretariat Secrétariat epi
Bayerstr. 83 Bayerstr. 83 Bayerstr. 83
80335 München 80335 Munich 80335 Munich
Deutschland Germany Allemagne
Tel. +49 (0)89 242052-0 Tel. +49 (0)89 242052-0 Tél. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20 Fax +49 (0)89 242052-20 Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.com info@patentepi.com info@patentepi.com

1
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Löwe, Ralf Stefan (DE) Lummer, Ingo Jörn (DE) Marchand, Philipp (DE)
Luye Pharma AG Hepp Wenger Ryffel AG Vossius & Partner
Bäumleingasse 22 Friedtalweg 5 Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
4051 BASEL 9500 WIL Nadelberg 3
4051 BASEL

Oertig, Rolf (CH) Pramberger, Karin (AT) Richter, Mirja (DE)


Schneider Feldmann AG cf. ES Sensirion AG
Patent- und Markenanwälte Swiss Pharma International Laubisruetistrasse 50
Postfach Waldmannstrsse 8 8712 STAEFA
Beethovenstrasse 49 8001 ZÜRICH
8027 ZÜRICH

Sbaragli, Laura (IT) Spiller, Erasmo (DE)


Novartis Pharma AG Maschinenfabrik Rieter AG
Postfach Intellectual Property
4002 BASEL Klosterstrasse 20
8406 WINTERTHUR

Änderungen Amendments Modifications Borne, Patrice Daniel (FR) Koelliker, Robert (CH) Vergani, Diego (CH)
Bugnion S.A. c/o Patentanwalt Koelliker GmbH Pharma Concepts GmbH
10, route de Florissant Bahnhofstrasse 11 Unterer Rheinweg 50
Case Postale 375 6210 SURSEE 4057 BASEL
1211 GENÈVE 12-CHAMPEL

Vesterinen, Jussi Tapio (FI) Wenger, Joel-Théophile (CH)


Lumi IP GmbH IP Partners J. Wenger
Jägerweg 12 Rte des Avouillons 6
3014 BERN 1196 GLAND

CZ Tschechische Czech République


Republik Republic tchèque

Eintragungen Entries Inscriptions Benda, Tomáš (CZ)


Kania, Sedlak, Smola
Patent Attorneys
Mendlovo namesti 1a
603 00 BRNO

DE Deutschland Germany Allemagne

Eintragungen Entries Inscriptions Abawi, Christian Farid (DE) Ackermann, Markus Korbinian (DE) Ammelburg, Jan Moritz (DE)
Mitscherlich PartmbB Ter Meer Steinmeister & Partner c/o Fish & Richardson P.C.
Patent- und Rechtsanwälte Patentanwälte mbB Highlight Business Towers
Sonnenstraße 33 Nymphenburger Straße 4 Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80331 MÜNCHEN 80335 MÜNCHEN 80807 MÜNCHEN

Aulich, Dennis Marc (DE) Bäder, Dirk Daniel (DE) Beck, Johannes Gerhard (DE)
Grünecker Haydnstraße 2 Gutenbergstraße 4
Patent- und Rechtsanwälte 70734 FELLBACH 80638 MÜNCHEN
PartG mbB
Kurfürstendamm 38/39
10719 BERLIN

Beckers, Simone (DE) Bläsi, Stefanie Lisa (DE) Boeckel, Moritz Tillmann (DE)
Richardt Patentanwälte PartG mbB IP2 Patentanwalts GmbH Boeckel Hollenberg Schröder
Wilhelmstraße 7 Schlossstraße 523-525 Patentanwälte PartG mbB
65185 WIESBADEN 41238 MÖNCHENGLADBACH Kahrstraße 4
45128 ESSEN

Boesecke, Christoph (DE) Bulat, Branimir (HR) Casper, Catharina (DE)


Liedtke & Partner df-mp Dörries Frank-Molnia & Winter, Brandl, Fürniss, Hübner
Patentanwälte Pohlman Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft
Gerhart-Hauptmann-Straße 10/11 Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
99096 ERFURT PartG mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Theatinerstraße 16 Bavariaring 10
80333 MÜNCHEN 80336 MÜNCHEN

Deis, Leo (DE) Dekker, Lothar Karl Rudolf (DE) Düsselberg, David (DE)
Robert Bosch GmbH Patentanwaltskanzlei Dekker Belsenstraße 21
Corporate Intellectual Property Friedensheimer Straße 26 40545 DÜSSELDORF
Wernerstraße 51 27729 VOLLERSODE
70469 STUTTGART

Ergenzinger, Christian Tobias (DE) Gleim, Christian Ragnar (DE) Goebel, Sebastian (DE)
c/o Kohler Schmid Möbus Gleim Petri Bals & Vogel
Patentanwälte Patent- und Patentanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Universitätsstraße 142
Gropiusplatz 10 Ludwigstraße 22 44799 BOCHUM
70563 STUTTGART 97070 WÜRZBURG

Grant, Anne (DE) Greiner, Gordon (DE) Grödl, Felix Veit (DE)
Hoffmann Eitle ratiopharm GmbH Bardehle Pagenberg Partnerschaft
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Graf-Arco-Straße 3 mbB
Arabellastraße 30 89079 ULM Patentanwälte, Rechtsanwälte
81925 MÜNCHEN Prinzregentenplatz 7
81675 MÜNCHEN

2
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Haas, Caroline (DE) Hagemann, Borys (DE) Hanke, Sebastian (DE)


Vossius & Partner Schiweck Weinzierl Koch Schulstraße 1
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Patentanwälte Partnerschaft mbB 38723 SEESEN
Siebertstraße 3 Ganghoferstraße 68B
81675 MÜNCHEN 80339 MÜNCHEN

Heckeler, Patrick (DE) Heitzer, Christian Michael (DE) Hildbrand, Christian (DE)
Bardehle Pagenberg Partnerschaft Klenzestraße 4 Robert Bosch GmbH
mbB 80496 MÜNCHEN Corporate Intellectual Property
Patentanwälte, Rechtsanwälte Wernerstraße 51
Prinzregentenplatz 7 70469 STUTTGART
81675 MÜNCHEN

Hirons, Daniel Stuart (GB) Hoffmann, Alexandre (LU) Imai, Yoshihito (JP)
Haseltine Lake LLP Bardehle Pagenberg Partnerschaft Müller-Boré & Partner
Bürkleinstraße 10 mbB Patentanwälte PartG mbB
80538 MÜNCHEN Patentanwälte, Rechtsanwälte Friedenheimer Brücke 21
Prinzregentenplatz 7 80639 MÜNCHEN
81675 MÜNCHEN

Jeong, Seung-Joo (KR) Jungclaus, Arndt (DE) Knoke, Isabel Yvonne (DE)
Vossius & Partner Kalkoff & Partner Meissner Bolte
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Patentanwälte Patentanwälte Rechtsanwälte
Siebertstraße 3 Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b Partnerschaft mbB
81675 MÜNCHEN 44227 DORTMUND Bankgasse 3
90402 NÜRNBERG

Kopczak, Jakub Jerzy (DE) Koukounis, Andrea (DE) Kraus, Christina Verena (DE)
TBK Vossius & Partner Leinweber & Zimmermann
Bavariaring 4-6 Patentanwälte und Rechtsanwälte Rosental 7
80336 MÜNCHEN mbB 80331 MÜNCHEN
Kaiserswerther Straße 229
40474 DÜSSELDORF

Laub, Hans Arnold (DE) Läufer, Christian (DE) Lavall, Christian Henner (DE)
Müller-Boré & Partner Fuchs John Deere GmbH & Co. KG
Patentanwälte PartG mbB Patentanwälte Partnerschaft mbB Global Intellectual Property Services
Friedenheimer Brücke 21 Westhafenplatz 1 John-Deere-Straße 70
80639 MÜNCHEN 60327 FRANKFURT AM MAIN 68163 MANNHEIM

Lehmacher, Marc (DE) Ley, Théodore Lionel Gérard (FR) Linhardt, Melanie Birgit (DE)
Seemüllerstraße 17 Olswang Germany LLP Prinz & Partner mbB
81549 MÜNCHEN Promenadeplatz 12 Patent- und Rechtsanwälte
80333 MÜNCHEN Rundfunkplatz 2
80335 MÜNCHEN

Lueg, Corinna (DE) Lüffe, Matthias (DE) Lütkebohmert, Christoph (DE)


Cohausz & Florack Maikowski & Ninnemann Witte, Weller & Partner
Patent- und Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Patentanwälte mbB
Partnerschaftsgesellschaft mbB Isartorplatz 5 Phoenixbau
Bleichstraße 14 80331 MÜNCHEN Königstraße 5
40211 DÜSSELDORF 70173 STUTTGART

Malescha, Florian (DE) Mania, Philipp (DE) Merkel, Sabine Anita (DE)
Jachenauerstraße 4 Continental AG ZF Friedrichshafen AG
81369 MÜNCHEN Patentabteilung Löwentaler Straße 20
Jädekamp 30 88046 FRIEDRICHSHAFEN
30419 HANNOVER

Meyer, Elisabeth Maria (DE) Meyer, Florian Alexander Marius Millahn, Manuel (DE)
Beckord & Niedlich (DE) Luisenstraße 55
Patentanwälte PartG mbB Meissner Bolte 80333 MÜNCHEN
Marktplatz 17 Patentanwälte Rechtsanwälte
83607 HOLZKIRCHEN Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 47
80538 MÜNCHEN

Mirabella, Edoardo (IT) Mohry, Thomas Friedrich (DE) Moonen, Pieter Frederik (NL)
Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Hauffstraße 10 BASF Coatings GmbH
mbB 70771 LEINFELDEN- Global Intellectual Property
Patent- und Rechtsanwälte ECHTERDINGEN Glasuritstraße 1
Steinerstraße 15/A 48165 MÜNSTER
81369 MÜNCHEN

Nöth, Richard Alexander Dieter (DE) Nowozin, Robert Tobias Heinrich Oancea, Andreas Christian (DE)
Paul & Albrecht (DE) Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB Bressel und Partner mbB Patentanwälte PartG mbB
Stresemannallee 4b Patentanwälte Schweigerstraße 2
41460 NEUSS Park Kolonnaden 81541 MÜNCHEN
Potsdamer Platz 10
10785 BERLIN

Otten, Marcus (DE) Pfaffeneder, Ines (DE) Pilger, Jens-Peter (DE)


c/o Samson & Partner Patentanwälte Maiwald Patentanwalts- und Dilg, Haeusler, Schindelmann
mbB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Patentanwaltsgesellschaft mbH
Widenmayerstraße 6 Elisenhof Leonrodstraße 58
80538 MÜNCHEN Elisenstraße 3 80636 MÜNCHEN
80335 MÜNCHEN

3
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Prantner, Marinus (DE) Rauch, Udo (DE) Reede, Alexander Karl (DE)
Nettelkofener Straße 2 1/2 Blumbach · Zinngrebe Feder Walter Ebert
85567 GRAFING Patent- und Rechtsanwälte Patentanwälte
PartG mbB Achenbachstraße 59
Alexandrastraße 5 40237 DÜSSELDORF
65187 WIESBADEN

Regler, Markus Egid (DE) Rigas, Ioannes (DE) Ritter, Steffen Markus (DE)
Benteler Automobiltechnik GmbH FDST Patentanwälte Part mbB Patentanwälte Ruff, Wilhelm,
An der Talle 27-31 Nordostpark 16 Beier, Dauster & Partner mbB
33102 PADERBORN 90411 NÜRNBERG Kronenstraße 30
70174 STUTTGART

Rotmann, Björn Paul André (DE/FR) Saxe, Frauke Katharina Sophie (DE) Schambach, Felix (DE)
Hoffmann Eitle Feder Walter Ebert Bobbert & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Patentanwälte Patentanwälte PartmbB
Arabellastraße 30 Achenbachstraße 59 Lange Zeile 13
81925 MÜNCHEN 40237 DÜSSELDORF 85435 ERDING

Schlenker, Julian (DE) Schmachtel, Rainer (DE) Schmid, Christian Hermann (DE)
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Voith GmbH & Co. KGaA Kramer - Barske - Schmidtchen
Zinkler, Schenk & Partner mbB Corporate IP Patentanwälte PartG mbB
Patentanwälte St. Pöltener Straße 43 Landsberger Straße 300
Radlkoferstraße 2 89522 HEIDENHEIM 80687 MÜNCHEN
81373 MÜNCHEN

Schmidt, Daniel (DE) Schramm, Thomas Harald (DE) Schwartze, Gregor Christoph (DE)
ZF Friedrichshafen AG Keil & Schaafhausen Bayer Intellectual Property GmbH
Gewerblicher Rechtsschutz ZF- Patent- und Rechtsanwälte Creative Campus Monheim
Konzern PartGmbB Alfred-Nobel-Straße 10
Graf-von-Soden-Platz 1 Friedrichstraße 2-6 40789 MONHEIM
88046 FRIEDRICHSHAFEN 60323 FRANKFURT AM MAIN

Siegel, Jan Philipp (DE) Spiegelhalder, Frederik Matthias Stingl, Torben Walter (DE)
Dr. Gassner & Partner mbB (DE) Robert Bosch GmbH
Patentanwälte FMS-IP Corporate Intellectual Property
Marie-Curie-Straße 1 Herzogstraße 59 Wernerstraße 51
91052 ERLANGEN 80803 MÜNCHEN 70469 STUTTGART

Sun, Boqiao (DE) Sünder, Philipp (DE) Tewary, Abhishek (IN)


Schiweck Weinzierl Koch Lorenz & Kopf PartG mbB Ter Meer Steinmeister & Partner
Patentanwälte Partnerschaft mbB Patentanwälte Patentanwälte mbB
Ganghoferstraße 68B LKGLOBAL Nymphenburger Straße 4
80339 MÜNCHEN Brienner Straße 11 80335 MÜNCHEN
80333 MÜNCHEN

Trautmann, Martin Tobias (DE) Türmer, Sebastian (DE) Walz, Irene (DE)
Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Giesecke+Devrient Mobile Security Grünecker
Pilgersheimer Straße 20 GmbH Patent- und Rechtsanwälte
81543 MÜNCHEN Prinzregentenstraße 159 PartG mbB
81677 MÜNCHEN Leopoldstraße 4
80802 MÜNCHEN

Warneke, Nicola (DE) Weber, Daniel Patrick (DE) Wehner, Johannes Hermann
Kanzlei Warneke SEW-Eurodrive GmbH & Co KG Winfried (DE)
Rechts- und Patentanwälte Ernst-Blickle-Straße 42 Dr. Wehner & Knapp
Leonrodstraße 11 76646 BRUCHSAL Patent- und
83278 TRAUNSTEIN Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Gewerbepark 3
36160 DIPPERZ

Werhahn, Jasper Carl (DE) Wildschütte, Matthias Bernd (DE) Wollschlaeger, Heinrich Jeremias
Meissner Bolte Pfister & Pfister Valentin (DE)
Patentanwälte Rechtsanwälte Patentanwälte Hoffmann Eitle
Partnerschaft mbB Hallhof 6-7 Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Widenmayerstraße 47 87700 MEMMINGEN Königsallee 106
80538 MÜNCHEN 40215 DÜSSELDORF

Wurm, Jürgen (DE) Wurth, Jonathan Johannes (DE) Zaus, Edgar (DE)
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Reitstötter Kinzebach & Partner Siemens Healthcare GmbH
Falkensteinstraße 8 Patentanwälte Intellectual Property
93059 REGENSBURG Im Zollhof 1 Hartmannstraße 16
67061 LUDWIGSHAFEN 91052 ERLANGEN

Zeiner, Johannes Michael (DE) Zerbes, Valentin (DE)


AAA-Patent Webasto SE
Heinrich-Barth-Straße 20 Kraillinger Straße 5
66115 SAARBRÜCKEN 82131 STOCKDORF

Änderungen Amendments Modifications Behrendt, Mona Gwendolyn (DE) Borbach, Markus (DE) Bradler, Carola Romana (DE)
Schiweck Weinzierl Koch Patentanwaltskanzlei Dr. Borbach Am Reitplatz 3
Patentanwälte Partnerschaft mbB Corneliusstraße 18 18107 ELMENHORST /
Ganghoferstraße 68B 60325 FRANKFURT LICHTENHAGEN
80339 MÜNCHEN

4
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Geissler, Andreas (DE) Gesthuysen, Hans Dieter (DE) Heim, Florian Andreas (DE)
Windeckstraße 66A Uhlandstraße 3 Wunderlich & Heim Patentanwälte
81375 MÜNCHEN 45129 ESSEN Partnerschaftsgesellschaft mbB
Irmgardstraße 3
81479 MÜNCHEN

Heim, Hans-Karl (DE) Huang, Xuting (CN) Jeschke, Alexander (DE)


Wunderlich & Heim Patentanwälte Am Alten Garten 2 Weidner Stern Jeschke
Partnerschaftsgesellschaft mbB 88048 FRIEDRICHSHAFEN Patentanwälte Partnerschaft mbB
Irmgardstraße 3 Universitätsallee 17
81479 MÜNCHEN 28359 BREMEN

Klickow, Hans-Henning (DE) Koch, Andreas (DE) Kohl, Fabian Hanno (DE)
Klickow & Wetzel PartGmbB Schiweck Weinzierl Koch Hafner & Kohl
Patentanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Jessenstraße 4 Ganghoferstraße 68B Schleiermacherstraße 25
22767 HAMBURG 80339 MÜNCHEN 90491 NÜRNBERG

Löser, Iris (DE) Manetto, Susanne (DE) Manzer, Anna Katharina (DE)
Patent Research and Consulting Schiweck Weinzierl Koch Am Bergsteig 5
Panoramastraße 44 Patentanwälte Partnerschaft mbB 81541 MÜNCHEN
69257 WIESENBACH Ganghoferstraße 68B
80339 MÜNCHEN

Morgenthum-Neurode, Mirko (DE) Nenning, Peter (DE) Pelzer, Heiko (DE)


c/o Saurer Spinning Solutions GmbH Zimmerstraße 3 Am Liesenfeld 7a
& Co. KG 04109 LEIPZIG 41812 ERKELENZ
Patentabteilung
Carlstraße 60
52531 ÜBACH-PALENBERG

Pioro, Hilary Livia (US) Raasch, Detlef (DE) Schiweck, Wolfram (DE)
Schiweck Weinzierl Koch Jones Day Schiweck Weinzierl Koch
Patentanwälte Partnerschaft mbB Nextower Patentanwälte Partnerschaft mbB
Ganghoferstraße 68B Thurn-und-Taxis-Platz 6 Ganghoferstraße 68B
80339 MÜNCHEN 60313 FRANKFURT AM MAIN 80339 MÜNCHEN

Schniedermeyer, Markus (DE) Schuster, Rainer Gunnar (DE) Smit, Marco (NL)
c/o Saurer Spinning Solutions GmbH Hafner & Kohl Continental Automotive GmbH
& Co. KG Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Sodener Straße 9
Patentabteilung Schleiermacherstraße 25 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS
Carlstraße 60 90491 NÜRNBERG
52531 ÜBACH-PALENBERG

Spiegl, Dirk Alexander (DE) Stratmann, Ernst (DE) Weidner, Ulrich (DE)
Schiweck Weinzierl Koch Strücker Weg 14 Weidner Stern Jeschke
Patentanwälte Partnerschaft mbB 40699 ERKRATH Patentanwälte Partnerschaft mbB
Ganghoferstraße 68B Arnstädter Straße 50
80339 MÜNCHEN 99096 ERFURT

Weinzierl, Gerhard (DE) Wetzel, Philipp (DE) Wingefeld, Renate (DE)


Schiweck Weinzierl Koch Klickow & Wetzel PartGmbB Dr. Nathan-Straße 15
Patentanwälte Partnerschaft mbB Patentanwälte 65366 GEISENHEIM
Ganghoferstraße 68B Jessenstraße 4
80339 MÜNCHEN 22767 HAMBURG

Wunderlich, Rainer (DE)


Wunderlich & Heim Patentanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Irmgardstraße 3
81479 MÜNCHEN

Löschungen Deletions Radiations Arnold, Klaus-Peter (DE) Berglechner, Fabian (DE) Frick, Gerhard (DE)
R. 154(1) R. 154(1) R. 154(1)
Deutsche Thomson OHG MayReiprich Harthausener Straße 18
European Patent Operations Patentanwälte 85630 GRASBRUNN
Karl-Wiechert-Allee 1D Am Wald 3
30625 HANNOVER 85354 FREISING

Schimek, Wolfgang Stefan (DE) Valentin, Joachim (DE)


R. 154(2)(a) R. 154(1)
Werner-von-Siemens-Straße 6 Hünfelder Straße 15
86159 AUGSBURG 60386 FRANKFURT AM MAIN

DK Dänemark Denmark Danemark

Eintragungen Entries Inscriptions Bærentsen, Ulrich Gramstrup (DK) Engenheiro Wagner Kristiansen, Mansfeld-Giese, Keld (DK)
Patentgruppen A/S Elizabeth Lopes (PT) Mansfeld CPH
Arosgaarden Novo Nordisk A/S Gyldenløvesgade 8, 4th
Aaboulevarden 31, 4. Corporate Patents 1369 COPENHAGEN
8000 AARHUS C Novo Allé 1
2880 BAGSVÆRD

Löschungen Deletions Radiations Heinrich, Bernd (DE)


R. 154(2)(a)
LM WP Patent Holding A/S
Jupitervej 6
6000 KOLDING

5
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

ES Spanien Spain Espagne

Eintragungen Entries Inscriptions Anglada Casamajor, Maria Carme Boue Gutierrez, Oscar (ES) Espiell Gomez, Ignacio (ES)
(ES) Durán-Corretjer, S.L.P. R. Volart Pons y Cia., S.L.
Medichem S.A. Còrsega, 329 Pau Claris, 77 2º 1ª
Fructuós Gelabert, 6-8 (Paseo de Gracia/Diagonal) 08010 BARCELONA
08970 SANT JOAN DESPÍ, 08037 BARCELONA
BARCELONA

López Mosquera, Cristina (ES) Rodriguez Novoa, Lorena (ES)


Ferrer Internacional, S.A. mAbxience Research, S.L.
Joan Buscallà, 1-9 Manuel Pombo Angulo, 28, 3rd floor
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS- 28050 MADRID
BARCELONA

Löschungen Deletions Radiations Hoic, Margarita Irene (DE) Pramberger, Karin (AT)
cf. GR cf. CH
ZBM Patents & Trademarks Medichem S.A.
Pl. Catalunya, 1, 2nd Floor Fructuós Gelabert, 6-8
08002 BARCELONA 08970 SANT JOAN DESPÍ,
BARCELONA

FI Finnland Finland Finlande

Eintragungen Entries Inscriptions Kiviniemi, Teemu Juri Tapio (FI) Zitting, Simo Juhana (FI)
Seppo Laine Oy Boco IP Oy Ab
Itämerenkatu 3A Itämerenkatu 5
00180 HELSINKI 00180 HELSINKI

FR Frankreich France France

Eintragungen Entries Inscriptions Baudin, Pierre (FR) Bompart, Marc (FR) Clerc, Magali Béatrice Christine (FR)
Cabinet Vidon Cabinet Gasquet Cabinet Lavoix
Brevets & Stratégie Les Pléiades nº 24C 2, place d'Estienne d'Orves
16b, rue de Jouanet Park Nord - Annecy 75441 PARIS CEDEX 09
B.P. 90333 74370 METZ-TESSY
35703 RENNES CEDEX 7

Cour, Pierre (FR) Daviot, Isabelle (FR) Demonda, Ghislain (FR)


cf. NL IXAS Conseil Cabinet Plasseraud
Cabinet Loyer & Abello 15, rue Emile Zola Parc Technologique du Canal
9, rue Anatole de la Forge 69002 LYON 9, avenue de l'Europe
75017 PARIS 31520 RAMONVILLE

Eap, Clémentine Bopha-Devy (FR) Forey, Kévin (FR) Girard, Vincent Thierry (FR)
Cabinet Plasseraud Ipside Cabinet Plasseraud
66, rue de la Chaussée d'Antin 6, impasse Michel Labrousse 66, rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09 31100 TOULOUSE 75440 PARIS CEDEX 09

Klecthka, Victoria Marie Aliénor (FR) Le Gall, François-Henri (FR) Le Layec, Arthur Yann Thomas (FR)
Cabinet Lavoix IPAZ Cabinet Debay
2, place d'Estienne d'Orves Parc les Algorithmes 126 Résidence Elysée 2
75441 PARIS CEDEX 09 Bâtiment Platon 18, avenue de la Jonchère
CS 70003 Saint Aubin 78170 LA CELLE SAINT CLOUD
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Lewis, Graham Matthew (GB) Loubet, Bruno Thomas (FR) Riou, Grégory Franck (FR)
cf. GB Marks & Clerk France Brevalex
J A Kemp Immeuble Visium 22, avenue Doyen Louis Weil
75, boulevard Haussmann 22, avenue Aristide Briand 38024 GRENOBLE CEDEX 1
75008 PARIS 94117 ARCUEIL CEDEX

Sablé, Benoît Alain (FR) Saurat, Thibault (FR) Toucas, Romain Yves Georges (FR)
Livbag SAS Valeo Systèmes Thermiques Cabinet Lavoix Lyon
10, route de Beuzit Service Propriété Industrielle 62, rue de Bonnel
29590 PONT DE BUIS ZA l'Agiot, 8 rue Louis Lormand 69448 LYON CEDEX 03
CS 80517 - La Verrière
78322 LE MESNIL SAINT DENIS
CEDEX

Tourbot, Gabriel (FR)


Cabinet Lavoix
155/157, cours Berriat
38028 GRENOBLE CEDEX 1

Änderungen Amendments Modifications Akdogan, Nurhak (FR) Aumonier, Sebastien (FR) Autissier, Marion (FR)
IPAZ Blackberry Cabinet Plasseraud
18, rue de la République Le colisée zac danton 5 Cours de Verdun
34000 MONTPELLIER 8, avenue de l'Arche 33000 BORDEAUX
92400 COURBEVOIE

Coquel, Jean-Marc (FR) Decobert, Ludivine Marie (FR) Delye, Alexandre (FR)
Cabinet Plasseraud IPAZ IPAZ
5 Cours de Verdun Parc les Algorithmes Parc les Algorithmes
33000 BORDEAUX Bâtiment Platon Bâtiment Platon
CS 70003 Saint Aubin CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

6
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Dong, Ying (CN) Fromen, Cécile (FR) Kingolo, Alain (FR)


IPAZ IPAZ IPAZ
Parc les Algorithmes 18, rue de la République Parc les Algorithmes
Bâtiment Platon 34000 MONTPELLIER Bâtiment Platon
CS 70003 Saint Aubin CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Legrand, Olivier (FR) Mouget-Goniot, Claire (FR) Mündler, François (FR)


IPAZ IPAZ IPAZ
Parc les Algorithmes Parc les Algorithmes Parc les Algorithmes
Bâtiment Platon Bâtiment Platon Bâtiment Platon
CS 70003 Saint Aubin CS 70003 Saint Aubin CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Pontet, Bernard (FR) Sagniez, Laure (FR) Timoney, Ian Charles Craig (GB)
IPAZ IPAZ 30, avenue du Bois
Parc les Algorithmes 16, rue Gaillon 78620 L'ETANG LA VILLE
Bâtiment Platon 75002 PARIS
CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Tirand, Lorraine Marie (FR) Zamouth, Coralie (FR)


Cabinet Germain & Maureau Brevalex
12, rue Boileau 95, rue d'Amsterdam
69006 LYON 75378 PARIS CEDEX 8

Löschungen Deletions Radiations Marcus, Thomas (FR) Thomas, Nadine (FR)


cf. BE R. 154(1)
Cabinet Plasseraud Brandon IP
66, rue de la Chaussée d'Antin 64, rue Tiquetonne
75440 PARIS CEDEX 09 75002 PARIS

GB Vereinigtes United Royaume-Uni


Königreich Kingdom

Eintragungen Entries Inscriptions Allsop, Timothy James (GB) Amin, Suchit Jayendra (GB) Bajjon, Alexander (GB)
Defence Intellectual Property Rights The IP Asset Partnership Ltd Schlich Limited
Poplar 2A - 2214 Prama House 9 St. Catherine's Road
MOD Abbey Wood (South) 267 Banbury Road LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX
BRISTOL BS34 8JH OXFORD OX2 7HT BN17 5HS

Beasley, Benjamin Oliver (GB) Buckley, Hannah Charlotte (GB) Cadman, Christopher James (GB)
Venner Shipley LLP J A Kemp Potter Clarkson LLP
200 Aldersgate 14 South Square The Belgrave Centre
LONDON EC1A 4HD Gray's Inn Talbot Street
LONDON WC1R 5JJ NOTTINGHAM NG1 5GG

Carr, Louise (GB) Carty, Gregory James (GB) Chua-Short, Alexandra Rachael Huei
Mewburn Ellis LLP Marks & Clerk LLP Fehn (GB)
City Tower 1 New York Street Potter Clarkson LLP
40 Basinghall Street MANCHESTER M1 4HD The Belgrave Centre
LONDON EC2V 5DE Talbot Street
NOTTINGHAM NG1 5GG

Chung, Hoi Kan (GB) Cobbold, Alistair John (GB) Cockerell, Andrew John (GB)
Reddie & Grose LLP Kilburn & Strode LLP D Young & Co
The White Chapel Building Lacon London Briton House
10 Whitechapel High Street 84 Theobalds Road Briton Street
LONDON E1 8QS LONDON WC1X 8NL SOUTHAMPTON SO14 3EB

Coleman, Victoria Jane (GB) Constable, Sean Christopher James Crawford, Harriet Rebecca (GB)
Kilburn & Strode LLP (GB) Gill Jennings & Every LLP
Lacon London Mewburn Ellis LLP The Broadgate Tower
84 Theobalds Road City Tower 20 Primrose Street
LONDON WC1X 8NL 40 Basinghall Street LONDON EC2A 2ES
LONDON EC2V 5DE

Cresswell, Ashley Frederick (GB) Crick, Alex (GB) Crow, Martin (GB)
Mewburn Ellis LLP EIP Carpmaels & Ransford LLP
22-24 Queen Square Fairfax House One Southampton Row
BRISTOL BS1 4ND 15 Fulwood Place LONDON WC1B 5HA
LONDON WC1V 6HU

Cuss, Steven Martin (GB) Daniels, Alison Sarah (GB) Docherty, Callum James (GB)
Cooley (UK) LLP Elkington and Fife LLP Withers & Rogers LLP
Dashwood Thavies Inn House Nicholas Wilson House
69 Old Broad Street 3-4 Holborn Circus Dormer Place
LONDON EC2M 1QS LONDON EC1N 2HA LEAMINGTON SPA CV32 5AE

Gallagher, David Thaddeus (GB) Galloway, Luke William (GB) Hartland, Christopher Brett (GB)
J A Kemp EIP Potter Clarkson LLP
CPC2 Building Suite 4, Level 6 The Belgrave Centre
Capital Park Broad Gate Talbot Street
CAMBRIDGE CB25 5XE 22-26 The Headrow NOTTINGHAM NG1 5GG
LEEDS LS1 8EQ

7
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Hau, Darren Jun Wai (GB) Headley, Timothy Quinlan (GB) Herrick, Peter David Edmund (GB)
Marks & Clerk LLP J A Kemp Carpmaels & Ransford LLP
1 New York Street 14 South Square One Southampton Row
MANCHESTER M1 4HD Gray's Inn LONDON WC1B 5HA
LONDON WC1R 5JJ

Hopes, Rhodri Thomas (GB) Howe, Nicholas James (GB) Hunter, Christopher Jack Owen (GB)
Carpmaels & Ransford LLP HGF Limited Venner Shipley LLP
One Southampton Row 4th Floor, Merchant Exchange 200 Aldersgate
LONDON WC1B 5HA 17-19 Whitworth Street West LONDON EC1A 4HD
MANCHESTER M1 5WG

Jackson, Rosemary Louise Hunter Jarrett, Daniel Phillip (GB) Jones, Nathan Philip (GB)
(GB) Kilburn & Strode LLP Kilburn & Strode LLP
Kilburn & Strode LLP Lacon London Lacon London
Lacon London 84 Theobalds Road 84 Theobalds Road
84 Theobalds Road LONDON WC1X 8NL LONDON WC1X 8NL
LONDON WC1X 8NL

Kanabus, Marta M. (PL) Kavanagh, Anthony Patrick (GB) Kelly, Robert Thomas (GB)
HGF Limited Carpmaels & Ransford LLP D Young & Co LLP
4th Floor, Merchant Exchange One Southampton Row 120 Holborn
17-19 Whitworth Street West LONDON WC1B 5HA LONDON EC1N 2DY
MANCHESTER M1 5WG

Kilner, Matthew Simon (GB) King, Scott Paul (GB) Laffan, Matthew John (GB)
Kilburn & Strode LLP Gill Jennings & Every LLP Abel & Imray
Lacon London The Broadgate Tower 3 Assembly Square
84 Theobalds Road 20 Primrose Street Britannia Quay
LONDON WC1X 8NL LONDON EC2A 2ES CARDIFF CF10 4PL

Le Mesurier, Sarah Jayne (GB) Leonard-Pugh, Eurion (GB) Linehan, Michael John (GB)
Boult Wade Tennant LLP QinetiQ Ltd Potter Clarkson LLP
Verulam Gardens Intellectual Property Department The Belgrave Centre
70 Gray's Inn Road Malvern Technology Centre Talbot Street
LONDON WC1X 8BT St Andrew's Road NOTTINGHAM NG1 5GG
MALVERN, WORCESTERSHIRE
WR14 3PS

Makepeace, Philippa Jane (GB) McKeon, John Michael (GB) Mitchell, Sarah Catherine (GB)
Gill Jennings & Every LLP Mewburn Ellis LLP Carpmaels & Ransford LLP
The Broadgate Tower City Tower One Southampton Row
20 Primrose Street 40 Basinghall Street LONDON WC1B 5HA
LONDON EC2A 2ES LONDON EC2V 5DE

Nation, Edward Louis (GB) Palmer, Lloyd (GB) Parry, Imogen Sophie (GB)
Abel & Imray Canon Europe Limited J A Kemp
3 Assembly Square 3 The Square 14 South Square
Britannia Quay Stockley Park Gray's Inn
CARDIFF CF10 4PL UXBRIDGE, MIDDLESEX UB11 1ET LONDON WC1R 5JJ

Pownall, Joanna Louise (GB) Pratt, Jonathan Charles (GB) Price, Joshua Benjamin James (GB)
HGF Limited Boult Wade Tennant LLP Gill Jennings & Every LLP
4th Floor, Merchant Exchange Verulam Gardens The Broadgate Tower
17-19 Whitworth Street West 70 Gray's Inn Road 20 Primrose Street
MANCHESTER M1 5WG LONDON WC1X 8BT LONDON EC2A 2ES

Raybould, Adam (GB) Richardson-Bullock, James Ridout, Joseph (GB)


Patents Department W/1/073 Sedgwick (GB) Cooley (UK) LLP
Jaguar Land Rover Limited Withers & Rogers LLP Dashwood
Abbey Road Nicholas Wilson House 69 Old Broad Street
Whitley Dormer Place LONDON EC2M 1QS
COVENTRY CV3 4LF LEAMINGTON SPA CV32 5AE

Sackville, Samuel William Grange Severs, John Henry (GB) Shi, Wei Wilma (GB)
(GB) Gill Jennings & Every LLP J A Kemp
Carpmaels & Ransford LLP The Broadgate Tower 14 South Square
One Southampton Row 20 Primrose Street Gray's Inn
LONDON WC1B 5HA LONDON EC2A 2ES LONDON WC1R 5JJ

Smith, Richard (GB) Thompson, Hugh Patrick George Tzeuton Tchangoum, Eric Olivier
Hoffmann Eitle Sreeves (GB) (FR)
Harmsworth House Boult Wade Tennant LLP Soteryah IP Ltd
13-15 Bouverie Street Verulam Gardens 27 Old Gloucester Street
LONDON EC4Y 8DP 70 Gray's Inn Road LONDON WC1N 3AX
LONDON WC1X 8BT

Varley, James Richard (GB) Walker-Smith, Samantha Lynelle Zhi Warwicker, Sophie (GB)
Venner Shipley LLP (GB) Graham Watt & Co LLP
200 Aldersgate Keltie LLP St. Botolph's House
LONDON EC1A 4HD No.1 London Bridge 7-9 St. Botolph's Road
LONDON SE1 9BA SEVENOAKS, KENT TN13 3AJ

Wild, Benjamin (GB) Woodward, Jonathon Rowan (GB) Woolley, Robert Huw (GB)
Gill Jennings & Every LLP Carpmaels & Ransford LLP Haseltine Lake LLP
The Broadgate Tower One Southampton Row Lincoln House, 5th Floor
20 Primrose Street LONDON WC1B 5HA 300 High Holborn
LONDON EC2A 2ES LONDON WC1V 7JH

8
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Änderungen Amendments Modifications Adams, Harvey Vaughan John (GB) Andrews, Martyn Peter (GB) Baldock, Sharon Claire (GB)
Carpmaels & Ransford LLP Oxford Nanopore Technologies Ltd. Boult Wade Tennant LLP
One Southampton Row Edmund Cartwright House Verulam Gardens
LONDON WC1B 5HA Oxford Science Park 70 Gray's Inn Road
4 Robert Robinson Avenue LONDON WC1X 8BT
OXFORD OX4 4GA

Baxter, Frances Rachel (GB) Binnie, Simon John (GB) Brown, Katherine Louise (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Bucks, Teresa Anne (GB) Burrell, William Nicholas (GB) Capewell, Adam Daniel (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Cavalier, Marcus Alexander Mawson Charig, Benjamin Robin (GB) Cornell, Clare Alison (GB)
(GB) Ocado Finnegan Europe LLP
Minerva Intellectual Property Bldgs 1 and 2 Finnegan, Henderson, Farabow,
Consultancy Ltd. Trident Place Garrett & Dunner LLP
The Old School House Mosquito Way 1 London Bridge
School Lane HATFIELD AL10 9UL LONDON SE1 9BG
STADHAMPTON, OXFORDSHIRE
OX44 7TR

Crawford, Olivia Jane (GB) Creek, Isobel Clare (GB) Draper, Martyn John (GB)
Haseltine Lake LLP The IP Asset Partnership Ltd Boult Wade Tennant LLP
Redcliff Quay Prama House Verulam Gardens
120 Redcliff Street 267 Banbury Road 70 Gray's Inn Road
BRISTOL BS1 6HU OXFORD OX2 7HT LONDON WC1X 8BT

Elkin, Malcolm David (GB) Evitt, Andrew Scott (GB) Fish, Susanna Joyce (GB)
Boult Wade Tennant LLP Greaves Brewster LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Copa House Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road Station Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT CHEDDAR BS27 3AH LONDON WC1X 8BT

Ford, Hazel (GB) Fyles, Julie Marie (GB) Frost, Alex John (GB)
Finnegan Europe LLP cf. Myint, Julie Marie (GB) Boult Wade Tennant LLP
Finnegan, Henderson, Farabow, Verulam Gardens
Garrett & Dunner LLP 70 Gray's Inn Road
1 London Bridge LONDON WC1X 8BT
LONDON SE1 9BG

Garlick, Laura Joanna (GB) Gibson, Sarah Jane (GB) Hardy, Rosemary (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Withers & Rogers LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Derwent House
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 150 Arundel Gate
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT SHEFFIELD S1 2FN

Hayes, Adrian Chetwynd (GB) Hicks, Emma Samantha (GB) Hicks, Paul Edward (GB)
Boult Wade Tennant LLP cf. Palmer, Emma Samantha (GB) Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Hyden, Martin Douglas (GB) Instone, Alicia Claire (GB) Jacobs, Jemma Rachel (GB)
Wynne-Jones, Lainé & James LLP CSY Herts Boult Wade Tennant LLP
Essex Place 1 Bishop Square Verulam Gardens
22 Rodney Road HATFIELD, HERTS. AL10 9NE 70 Gray's Inn Road
CHELTENHAM GL50 1JJ LONDON WC1X 8BT

Jinks, Samuel (GB) Johnson, William Benjamin (GB) Kahn, Simon (GB)
Reddie & Grose LLP Oxford Nanopore Technologies Ltd. Boult Wade Tennant LLP
The White Chapel Building Gosling Building Verulam Gardens
10 Whitechapel High Street Edmund Halley Road 70 Gray's Inn Road
LONDON E1 8QS Oxford Science Park LONDON WC1X 8BT
OXFORD OX4 4DQ

Kennington, Eric Alasdair (GB) Kirk, Martin John (GB/IE) Lee, Andrew (GB)
CSY Herts DuPont Teijin Films (UK) Limited BAE Systems plc.
1 Bishop Square The Wilton Centre IP & TL
HATFIELD, HERTS. AL10 9NE REDCAR TS10 4RF Warwick House
Farnborough Aerospace Centre
FARNBOROUGH, HANTS.
GU14 6YU

Legg, James Christopher (GB) Mackenzie, Andrew Bryan (GB) Maughan, Sophie Louise (GB)
Boult Wade Tennant LLP CSY Herts CSY Herts
Verulam Gardens 1 Bishop Square 1 Bishop Square
70 Gray's Inn Road HATFIELD, HERTS. AL10 9NE HATFIELD, HERTS. AL10 9NE
LONDON WC1X 8BT

9
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

McFarlane, Joshua (GB) McLeish, Nicholas Alistair Maxwell Mercer, Daniel John (GB)
Boult Wade Tennant LLP (GB) Definition IP Limited
Verulam Gardens Boult Wade Tennant LLP The Core
70 Gray's Inn Road Verulam Gardens Newcastle Helix
LONDON WC1X 8BT 70 Gray's Inn Road Bath Lane
LONDON WC1X 8BT NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 5TF

Merchant, Philip Lloyd Herbert (GB) Merrifield, Sarah Elizabeth (GB) Midgley, Jonathan Lee (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP CSY Herts
Verulam Gardens Verulam Gardens 1 Bishop Square
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road HATFIELD, HERTS. AL10 9NE
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Morse, Edward James (GB) Murphy, Olivia Jane (GB) Myint, Julie Marie (GB)
Boult Wade Tennant LLP cf. Crawford, Olivia Jane (GB) Symbiosis IP Limited
Verulam Gardens Basepoint Business Centre
70 Gray's Inn Road Vale Business Park
LONDON WC1X 8BT Crab Apple Way
EVESHAM WR11 1GP

O'Farrell, Jennifer Mary (GB) Palmer, Emma Samantha (GB) Palmer, Jonathan R. (GB)
Boult Wade Tennant LLP Forresters IP LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Rutland House Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 148 Edmund Street 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT BIRMINGHAM B3 2JA LONDON WC1X 8BT

Peak, Joanna Caroline (GB) Pelly, Jason Charles (GB) Pelly, Joanna Louise (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Penny, Daryl (GB) Pluckrose, Anthony William (GB) Ponsford, Heather Fiona (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Pratt, Michelle Diane (GB) Ridley, Matthew Edward Waller (GB) Ronan, Edward (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Russell, Victoria Helen (GB) Rutherford, Claire (GB) Rutt, Jason Edward (GB)
Boult Wade Tennant LLP Definition IP Limited Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens The Core Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road Newcastle Helix 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT Bath Lane LONDON WC1X 8BT
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 5TF

Rutt, Oliver John (GB) Sands, Howard Simon (GB) Scott, Stephen John (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP YUJA Limited
Verulam Gardens Verulam Gardens Suite 4, Level 6
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road Broad Gate
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT 22-26 The Headrow
LEEDS LS1 8EQ

Setna, Rohan P. (GB) Short, James (GB) Sims, Marcus John (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Spencer, Matthew Peter (GB) Stevens, Naomi Rosalie (GB) Talbot-Ponsonby, Clare Josephine
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP (GB)
Verulam Gardens Verulam Gardens Boult Wade Tennant LLP
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road Verulam Gardens
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT

Thomson, Neil David (GB) Tucker, Nigel P. (GB) Walker, Philip Martin (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Dyson Technology Limited
Verulam Gardens Verulam Gardens Tetbury Hill
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road MALMESBURY, WILTSHIRE
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT SN16 0RP

Wall, Leythem (GB) Ward, Siobhan (GB) Weston, Daniel Roger (GB)
Finnegan Europe LLP Oxford Nanopore Technologies Ltd. Boult Wade Tennant LLP
Finnegan, Henderson, Farabow, Edmund Cartwright House Verulam Gardens
Garrett & Dunner LLP 4 Robert Robinson Avenue 70 Gray's Inn Road
1 London Bridge Oxford Science Park LONDON WC1X 8BT
LONDON SE1 9BG OXFORD OX4 4GA

10
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

White, Nina Louise (GB) Widdowson, Nicholas Edward (GB) Wortley, David Jonathan (GB)
Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP Boult Wade Tennant LLP
Verulam Gardens Verulam Gardens Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road 70 Gray's Inn Road
LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT LONDON WC1X 8BT

Löschungen Deletions Radiations Lewis, Graham Matthew (GB) Milnes, Rodger (GB) Newman, Alastair James Morley
cf. FR R. 154(1) (GB)
J A Kemp 43 Knox Road R. 154(1)
14 South Square GUILDFORD, SURREY GU2 9AH J A Kemp
Gray's Inn 14 South Square
LONDON WC1R 5JJ Gray's Inn
LONDON WC1R 5JJ

Perkins, Janet Frances (GB) Semos, Robert Ernest Vickers (GB)


R. 154(1) R. 154(1)
J A Kemp BT Intellectual Property Department
14 South Square Ground Floor
Gray's Inn BT Faraday Building
LONDON WC1R 5JJ 1 Knightrider Street
LONDON EC4V 5BT

GR Griechenland Greece Grèce

Eintragungen Entries Inscriptions Hoic, Margarita Irene (DE)


cf. ES
BIC
Aghiou Athanasiou St.
145 69 ANIXI

IE Irland Ireland Irlande

Änderungen Amendments Modifications Gillespie, Richard (IE)


Inventorship
Suite 10050
5 Fitzwilliam Square
DUBLIN 2, D02 R744

IS Island Iceland Islande

Änderungen Amendments Modifications Sigurgeirsson, Gunnar H. (IS)


Suite 10-A
Bodagranda 7
107 REYKJAVIK

IT Italien Italy Italie

Eintragungen Entries Inscriptions Cicchetti, Angelo (IT)


Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 TORINO

Änderungen Amendments Modifications Crucitti, Giuseppe (IT) Masala, Gian Tomaso (IT) Riccardi, Elisa (IT)
STMicroelectronics S.r.l. Notarbartolo & Gervasi S.p.A. ADV IP S.r.l.
Via C. Olivetti, 2 Corso di Porta Vittoria, 9 Corso di Porta Vittoria, 29
20864 AGRATE BRIANZA 20122 MILANO 20122 MILANO

Löschungen Deletions Radiations Arena, Giovanni (IT)


R. 154(1)
Viale Certosa, 135
20151 MILANO

LI Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein

Eintragungen Entries Inscriptions Schwärzler, Mark (CH)


Patentbüro Paul Rosenich AG
BGZ
Rotenbodenstrasse 12
9497 TRIESENBERG

LT Litauen Lithuania Lituanie

Änderungen Amendments Modifications Jason, Marius Jakulis (LT) Klimaitiene, Otilija (LT) Pakeniene, Ausra (LT)
AAA Law AAA Law AAA Law
P.O. Box 33 P.O. Box 33 P.O. Box 33
A. Goštauto street 40B A. Goštauto street 40B A. Goštauto street 40B
03163 VILNIUS 03163 VILNIUS 03163 VILNIUS

Petniunaite, Jurga (LT)


AAA Law
P.O. Box 33
A. Goštauto street 40B
03163 VILNIUS

11
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

NL Niederlande Netherlands Pays-Bas

Eintragungen Entries Inscriptions Hoeben, Johan Sebastiaan Fredrik Pastwa, Johannes (NL) Postmus, Bart (NL)
(NL) SABIC Limburg B.V. NLO
Patentwerk B.V. Europaboulevard 1 New Babylon City Offices
Julianaplein 4 6135 LD SITTARD Anna van Buerenplein 21a
5211 BC 'S-HERTOGENBOSCH 2595 DA DEN HAAG

Stegeman, Dick (NL) Van Dongen, Stijn Franciscus Maria van Zoelen, Wendy (NL)
EDP Patent Attorneys B.V. (NL) Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C)
Bronland 12E NLO Sir Winston Churchilllaan 295a
6708 WH WAGENINGEN New Babylon City Offices 2288 DC RIJSWIJK
Anna van Buerenplein 21a
2595 DA DEN HAAG

Vazquez Vazquez, Miriam (ES) Vidal Gonçalves, Estela (PT)


NLO NLO
Kennedyplein 236 New Babylon City Offices
5611 ZT EINDHOVEN Anna van Buerenplein 21a
2595 DA DEN HAAG

Änderungen Amendments Modifications de Cock, Eric Hubertus Augusta (NL) Einerhand, Markus Peter W. (NL) Elmore, Tamara (US)
Tata Steel Nederland Technology V.O. V.O.
B.V. Winthontlaan 6, 4th floor Winthontlaan 6, 4th floor
Group Intellectual Property Services 3526 KV UTRECHT 3526 KV UTRECHT
3G.37
Wenckebachstraat 1
1951 JZ VELSEN-NOORD

van der Maarl, Arjan (NL) Visscher, Inge (NL)


Gemeas Patents Astellas BV
Belleperenlaan 18 Sylviusweg 62
3452 EV UTRECHT PO Box 344
2300 AH LEIDEN

Löschungen Deletions Radiations Cour, Pierre (FR)


cf. FR
Philips Lighting B.V.
Philips Lighting Intellectual Property
High Tech Campus 45
5656 AE EINDHOVEN

NO Norwegen Norway Norvège

Eintragungen Entries Inscriptions Bauman, Anja Berge (NO)


Acapo AS
Strandgaten 198
5004 BERGEN

PL Polen Poland Pologne

Änderungen Amendments Modifications Kaczur-Kaczyńska, Ewa (PL) Matyka, Małgorzata (PL) Schimmelpfennig, Iwona (PL)
Politechnika Łódzka Kancelaria Prawno-Patentowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Rzecznik Patentowy Małgorzata Matyka Pulawy S.A.
ul. Wólczańska 223 bud.B17 ul. Zielony Stok 12/1U Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13
90-924 ŁÓDŹ 80-119 GDAŃSK 24-110 PULAWY

Suszek, Aleksander (PL)


Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Pulawy S.A.
Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13
24-110 PULAWY

SE Schweden Sweden Suède

Eintragungen Entries Inscriptions Ahlgren, Malin (SE) Blurock, Maryna (SE) Démoulin, Eva Lotta (SE)
Ström & Gulliksson AB Zacco Sweden AB Zacco Sweden AB
Carlsgatan 3 Mobilvägen 10 Valhallavägen 117 N
211 20 MALMÖ 223 62 LUND P.O. Box 5581
114 85 STOCKHOLM

Engquist, Johan (SE) Farieta, Jaime Antonio (SE) Girdzijauskas, Ivana (SE)
Ceraloc Innovation AB SHL Group AB Ericsson AB
Prästavägen 513 PO Box 1240 Torshamnsgatan 23
263 65 VIKEN Augustendalsvägen 7 164 83 STOCKHOLM
131 28 NACKA STRAND

Nordkvist, Johan Mattias (SE) Rydenius, Åsa Victoria (SE) Wallin, Ulf Mats Oscar (SE)
Arcam AB DeLaval International AB Husqvarna AB
Krokslätts Fabriker 27A Gustaf de Lavals väg 11 Jons väg 19
431 37 MÖLNDAL 147 41 TUMBA 433 75 JONSERED

Zheng, Linlin (CN)


AWA Sweden AB
Junkersgatan 1
582 35 LINKÖPING

12
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A76

Vertragsstaat
Contracting state
État contractant

Änderungen Amendments Modifications Blidefalk, Jenny (SE) Lundquist, Tomas (SE)


Mycronic AB Swedish Orphan Biovitrum AB
P.O. Box 3141 112 76 STOCKHOLM
183 03 TÄBY

TR Türkei Turkey Turquie

Eintragungen Entries Inscriptions Hamamcioğlu, Volkan (TR) Taş, Emrah (TR)


Arçelik A.Ş. Tritech Patent Trademark
Fikri Haklar Yöneticiliği Consultancy Inc
34950 TUZLA ISTANBUL Çankaya Mh. Mahmut Yesari Sk.
No. 8/5
06690 ÇANKAYA/ANKARA

Änderungen Amendments Modifications Sezgin, Hatice Özlem (TR) Yuce, Serfinaz Sibel (TR)
Demiron IP Inc. Efor Intellectual Property Law Ltd.
Baris Mah. Defne Sk. Defne Apt. Buyukdere Caddesi 30/5
No:10 K:4 D:8 Nilüfer Mecidiyekoy
16140 BURSA 34394 SISLI - ISTANBUL

13
Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 2018, A77

Hinweise für die Zahlung von Guidance for the payment of Avis concernant le paiement des
Gebühren, Auslagen und fees, expenses and prices taxes, redevances et tarifs de
Verkaufspreisen vente
Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis The fees guidance currently applicable Le texte de l'avis actuellement
ergibt sich aus ABl. EPA 2018, A32. is set out in OJ EPO 2018, A32. applicable est publié au JO OEB
2018, A32.
Das derzeit geltende Verzeichnis der The current schedule of fees and Le barème actuel des taxes et
Gebühren und Auslagen des EPA expenses of the EPO is set out in redevances de l'OEB figure dans la
ergibt sich aus der Zusatzpublikation 2, supplementary publication 2, publication supplémentaire 2,
ABl. EPA 2018. OJ EPO 2018. JO OEB 2018.
Gebühreninformationen sind auch Fee information is also published on Des informations concernant les
im Internet unter the EPO website: www.epo.org/fees. taxes sont également publiées à
www.epo.org/gebuehren l'adresse Internet
veröffentlicht. www.epo.org/taxes.

Vous aimerez peut-être aussi